-
MEDIX MEDICAL SERVICES EUROPE LIMITED - 4th Floor 118 Piccadilly Street, Mayfair, London, W1J 7NW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07458562
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4th Floor 118 Piccadilly Street
- Mayfair
- London
- W1J 7NW 4th Floor 118 Piccadilly Street, Mayfair, London, W1J 7NW UK
Management
- Geschäftsführung
- ATZMON LIDAR, Sigal
- JORDAN, Agnieszka Danuta
- ZELTZER, David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.12.2010
- Alter der Firma 2010-12-02 13 Jahre
- SIC/NACE
- 86900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Abraham Elkayam
- Mrs Sigal Atzmon Lidar
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-02
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-16
- Letzte Einreichung: 2023-12-02
-
MEDIX MEDICAL SERVICES EUROPE LIMITED Firmenbeschreibung
- MEDIX MEDICAL SERVICES EUROPE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07458562. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.12.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86900" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 02.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 4Th Floor 118 Piccadilly Street erreicht werden.
Jetzt sichern MEDIX MEDICAL SERVICES EUROPE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Medix Medical Services Europe Limited - 4th Floor 118 Piccadilly Street, Mayfair, London, W1J 7NW, Grossbritannien
- 2010-12-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MEDIX MEDICAL SERVICES EUROPE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-02-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-12-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-08) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-11-16) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-11-16) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-09-27) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-12-13) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-12-13) - PSC04
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-12-16) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-16) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-08-05) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-04-21) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-21) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-12-21) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-04) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-12-01) - MG01
-
legacy (2011-11-18) - MG01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-03-21) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-03-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-02) - NEWINC