-
WESTGATE COIL AND PROCESSING LIMITED - Westgate House Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, WS9 8BG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07455979
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Westgate House Middlemore Lane West
- Aldridge
- Walsall
- WS9 8BG Westgate House Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, WS9 8BG UK
Management
- Geschäftsführung
- GOULD, Darren William
- HATTERSLEY, Andrew Michael
- MOUNTFORD, Gary Lee
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.12.2010
- Alter der Firma 2010-12-01 13 Jahre
- SIC/NACE
- 25610
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Darren William Gould
- -
- Mr Gary Lee Mountford
- Mr Andrew Michael Hattersley
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-02-28
- Letzte Einreichung: 2023-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-01
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-06
- Letzte Einreichung: 2023-07-23
-
WESTGATE COIL AND PROCESSING LIMITED Firmenbeschreibung
- WESTGATE COIL AND PROCESSING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07455979. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.12.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "25610" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 29/02/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 01.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Westgate House Middlemore Lane West erreicht werden.
Jetzt sichern WESTGATE COIL AND PROCESSING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Westgate Coil And Processing Limited - Westgate House Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, WS9 8BG, Grossbritannien
- 2010-12-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WESTGATE COIL AND PROCESSING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-10-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-04-27) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2021-07-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2020-12-03) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-11) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-11-14) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-08-07) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-10-22) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-10-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-24) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-24) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-01) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-01-09) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-16) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
resolution (2012-04-03) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-04-23) - AA01
-
capital-name-of-class-of-shares (2012-04-03) - SH08
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-10) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
resolution (2011-02-18) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name (2011-12-21) - TM01
-
resolution (2011-12-21) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2011-12-20) - SH06
-
resolution (2011-12-20) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2011-12-20) - SH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-13) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-12-13) - TM02
-
legacy (2011-02-24) - MG01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-12-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-12-21) - CH01
-
incorporation-company (2010-12-01) - NEWINC