-
PIERCE MANAGEMENT SERVICES LIMITED - Ground Floor 8 St. Georges Court, Dairyhouse Lane, Broadheath, Altrincham, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07453337
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ground Floor 8 St. Georges Court, Dairyhouse Lane
- Broadheath
- Altrincham
- Cheshire
- WA14 5UA Ground Floor 8 St. Georges Court, Dairyhouse Lane, Broadheath, Altrincham, Cheshire, WA14 5UA UK
Management
- Geschäftsführung
- ALBERGA, Simon Julian
- HARRIS, Peter Anthony
- LEDSON, Thomas Paul Johnson
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-29 13 Jahre
- SIC/NACE
- 62020
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Micad Systems (Uk) Limited
- Pierce Assets Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-29
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-13
- Letzte Einreichung: 2020-11-29
-
PIERCE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- PIERCE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07453337. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.11.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62020" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 29.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Ground Floor 8 St. Georges Court, Dairyhouse Lane erreicht werden.
Jetzt sichern PIERCE MANAGEMENT SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pierce Management Services Limited - Ground Floor 8 St. Georges Court, Dairyhouse Lane, Broadheath, Altrincham, Cheshire, Grossbritannien
- 2010-11-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PIERCE MANAGEMENT SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-01-21) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-05-11) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-01-20) - PSC05
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-03-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-02) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-05-31) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-05-29) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-04-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-04-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-01) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-10-31) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-15) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-19) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-15) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-30) - AR01
-
resolution (2015-06-22) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-15) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-27) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-13) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-13) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-08-01) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-11-02) - CH01
-
termination-director-company-with-name (2011-10-28) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-29) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-11-30) - AA01