-
JEFFERIES SOLICITORS LIMITED - The Triangle, 1st Floor, 8 Cross Street, Altrincham, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07451340
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Triangle, 1st Floor
- 8 Cross Street
- Altrincham
- Cheshire
- WA14 1EQ
- England The Triangle, 1st Floor, 8 Cross Street, Altrincham, Cheshire, WA14 1EQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MAXEY, James Thomas
- SLADE, Daniel Adam
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-25 13 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Express Solicitors Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-12-09
- Letzte Einreichung: 2022-11-25
-
JEFFERIES SOLICITORS LIMITED Firmenbeschreibung
- JEFFERIES SOLICITORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07451340. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.11.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.11.2012.Die Firma kann schriftlich über The Triangle, 1St Floor erreicht werden.
Jetzt sichern JEFFERIES SOLICITORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jefferies Solicitors Limited - The Triangle, 1st Floor, 8 Cross Street, Altrincham, Cheshire, Grossbritannien
- 2010-11-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JEFFERIES SOLICITORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-07-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-07-27) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-07-27) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-07-27) - PSC02
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2023-07-27) - TM02
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-06) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-25) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-13) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-30) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-15) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-08-20) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-11-08) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-07-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-19) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-06-13) - SH01
-
resolution (2012-06-13) - RESOLUTIONS
-
legacy (2012-06-01) - MG01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2012-02-24) - RP04
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-02-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-15) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-12-15) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-06-16) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-06-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-25) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2010-12-02) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-12-14) - AD01