-
VAYON VEHICLE TECHNOLOGIES LIMITED - C/O Begbies Traynor 29th Floor 40, Bank Street, London, E14 5NR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07448420
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Begbies Traynor 29th Floor 40
- Bank Street
- London
- E14 5NR C/O Begbies Traynor 29th Floor 40, Bank Street, London, E14 5NR UK
Management
- Geschäftsführung
- HUSSAIN, Shahid
- Prokuristen
- MCNICOLL, Alexander Robert
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-23 13 Jahre
- SIC/NACE
- 29310
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- FROST EV SYSTEMS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-09-30
- Letzte Einreichung: 2014-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-12-07
- Letzte Einreichung:
-
VAYON VEHICLE TECHNOLOGIES LIMITED Firmenbeschreibung
- VAYON VEHICLE TECHNOLOGIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07448420. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.11.2010 registriert. VAYON VEHICLE TECHNOLOGIES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FROST EV SYSTEMS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "29310" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2014 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.11.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o Begbies Traynor 29Th Floor 40 erreicht werden.
Jetzt sichern VAYON VEHICLE TECHNOLOGIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vayon Vehicle Technologies Limited - C/O Begbies Traynor 29th Floor 40, Bank Street, London, E14 5NR, Grossbritannien
- 2010-11-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VAYON VEHICLE TECHNOLOGIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-01-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-07-22) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-01-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-01-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-01-28) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-01-12) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-disclaimer-notice (2017-04-08) - F10.2
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-11-24) - 600
-
certificate-change-of-name-company (2016-01-31) - CERTNM
-
miscellaneous (2016-02-03) - MISC
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-06-05) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-06-05) - TM02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-06-23) - MR01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-11-24) - 4.20
-
resolution (2016-11-24) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2016-01-31) - CONNOT
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-28) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-19) - AA
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-10-08) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-02) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-02) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-14) - AD01
-
capital-allotment-shares (2014-03-27) - SH01
-
resolution (2014-04-08) - RESOLUTIONS
-
resolution (2014-04-24) - RESOLUTIONS
-
resolution (2014-04-30) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2014-04-30) - MEM/ARTS
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-04-30) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-04-24) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-30) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-30) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-07-03) - AP03
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-08-04) - AA01
-
capital-allotment-shares (2014-04-30) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-31) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-09-30) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-04-07) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-23) - NEWINC