-
TENDERCAPITAL LIMITED - 42 Brook Street, London, W1K 5DB, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07440143
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 42 Brook Street
- London
- W1K 5DB
- United Kingdom 42 Brook Street, London, W1K 5DB, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- CAMPONOVO, Stefano
- CHIARINI, Alessandro
- ZANI, Moreno
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-15 13 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Moreno Zani
- -
- Two Elle Group Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- CAPITAL TENDER LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 254900PLZGJFIQRJ0I32
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-10
- Letzte Einreichung: 2020-06-26
-
TENDERCAPITAL LIMITED Firmenbeschreibung
- TENDERCAPITAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07440143. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.11.2010 registriert. TENDERCAPITAL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CAPITAL TENDER LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.11.2012.Die Firma kann schriftlich über 42 Brook Street erreicht werden.
Jetzt sichern TENDERCAPITAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tendercapital Limited - 42 Brook Street, London, W1K 5DB, United Kingdom, Grossbritannien
- 2010-11-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TENDERCAPITAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-09-21) - PSC02
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-02-11) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-20) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-17) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-09-21) - PSC07
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-12-05) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-10) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-10) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-10) - PSC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-09-03) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-17) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-15) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-15) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-16) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-11) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-10-19) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-18) - AR01
-
resolution (2015-09-29) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-05-08) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-05-02) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-10-02) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-19) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2013-07-18) - CERTNM
-
certificate-change-of-name-company (2013-07-17) - CERTNM
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-07-09) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-05-07) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-04-22) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-18) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-17) - AP01
-
legacy (2013-02-13) - MG01
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-01-13) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-02-15) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-04-18) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-12-10) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-13) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-12-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-12-07) - AA01
-
capital-allotment-shares (2011-10-07) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-10-07) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-15) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2010-11-17) - CERTNM