-
SPHERE PROJECTS LTD - Unit 1 Ty Nant Court, Morganstown, Cardiff, CF15 8LW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07429652
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 1 Ty Nant Court
- Morganstown
- Cardiff
- CF15 8LW
- United Kingdom Unit 1 Ty Nant Court, Morganstown, Cardiff, CF15 8LW, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- HUGHES, James Grant
- HUGHES, Rachel Victoria
- PARSONS, James Edward
- PARSONS, Kelly
- Prokuristen
- HUGHES, Rachel Victoria
- PARSONS, Kelly
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-04 13 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr James Grant Hughes
- Mrs Rachel Hughes
- Mr James Edward Parsons
- Mrs Kelly Parsons
- Mrs Rachel Hughes
- Mrs Kelly Parsons
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-19
- Letzte Einreichung: 2020-11-05
-
SPHERE PROJECTS LTD Firmenbeschreibung
- SPHERE PROJECTS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07429652. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.11.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 2 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 1 Ty Nant Court erreicht werden.
Jetzt sichern SPHERE PROJECTS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sphere Projects Ltd - Unit 1 Ty Nant Court, Morganstown, Cardiff, CF15 8LW, Grossbritannien
- 2010-11-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SPHERE PROJECTS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-23) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-11-26) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2019-11-14) - CH03
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-14) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-11-14) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-06) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-16) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-09-12) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-06) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-05-03) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-26) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-11-23) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-10-21) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-07-29) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-05) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-10-23) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-01-27) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-01-27) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-02-11) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-22) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-17) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-16) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-12-01) - AP03
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-01) - CH01
-
capital-allotment-shares (2014-07-10) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-09) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-08-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-04) - AA
-
legacy (2012-10-27) - MG01
-
legacy (2012-11-15) - MG01
-
legacy (2012-12-04) - MG02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-31) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-07-20) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-07-20) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-05-23) - AA01
-
capital-allotment-shares (2011-05-05) - SH01
-
legacy (2011-01-06) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-04) - NEWINC