-
N E C ENGINEERING LIMITED - Unit 8 Glover Centre Egmont Street, Mossley, Ashton-Under-Lyne, Lancs, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07417283
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 8 Glover Centre Egmont Street
- Mossley
- Ashton-Under-Lyne
- Lancs
- OL5 9PY Unit 8 Glover Centre Egmont Street, Mossley, Ashton-Under-Lyne, Lancs, OL5 9PY UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.10.2010
- Alter der Firma 2010-10-25 13 Jahre
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Martin Rigby
- Mr Mark Burns
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- HIPPO'S TAKEAWAY LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-11-30
- Letzte Einreichung: 2023-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-01
- Letzte Einreichung: 2023-04-17
-
N E C ENGINEERING LIMITED Firmenbeschreibung
- N E C ENGINEERING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07417283. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.10.2010 registriert. N E C ENGINEERING LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HIPPO'S TAKEAWAY LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 29/02/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Unit 8 Glover Centre Egmont Street erreicht werden.
Jetzt sichern N E C ENGINEERING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: N E C Engineering Limited - Unit 8 Glover Centre Egmont Street, Mossley, Ashton-Under-Lyne, Lancs, Grossbritannien
- 2010-10-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu N E C ENGINEERING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2024-02-13) - PSC07
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-04-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-08-01) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-04-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-20) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-10-28) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-08-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-03-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-03-09) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-01-10) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-30) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2016-01-06) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-19) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-29) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-09-15) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-01) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-02) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-14) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-16) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-01-27) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-07) - AA
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2015-02-09) - RP04
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-29) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-02-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-02-21) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-25) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-01-17) - AP01
-
capital-allotment-shares (2011-01-17) - SH01
-
legacy (2011-01-18) - MG01
-
legacy (2011-01-20) - MG01
-
certificate-change-of-name-company (2011-01-18) - CERTNM
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-03-14) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-20) - AR01
-
change-of-name-notice (2011-01-18) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-10-25) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2010-10-25) - TM01