-
DJ COOPER ENTERPRISES LIMITED - Xl Business Solutions Premier House, Bradford Road, Cleckheaton, BD19 3TT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07410112
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Xl Business Solutions Premier House
- Bradford Road
- Cleckheaton
- BD19 3TT Xl Business Solutions Premier House, Bradford Road, Cleckheaton, BD19 3TT UK
Management
- Geschäftsführung
- JANEZ DEL AMO, Federico
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.10.2010
- Alter der Firma 2010-10-18 13 Jahre
- SIC/NACE
- 46390
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Khalid Mahmood
- Mr Frederico Janez Del Amo
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- COOPER ACCOUNTING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-07-31
- Letzte Einreichung: 2017-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-12-13
- Letzte Einreichung: 2018-11-29
-
DJ COOPER ENTERPRISES LIMITED Firmenbeschreibung
- DJ COOPER ENTERPRISES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07410112. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.10.2010 registriert. DJ COOPER ENTERPRISES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen COOPER ACCOUNTING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46390" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2017 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Xl Business Solutions Premier House erreicht werden.
Jetzt sichern DJ COOPER ENTERPRISES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dj Cooper Enterprises Limited - Xl Business Solutions Premier House, Bradford Road, Cleckheaton, BD19 3TT, Grossbritannien
- 2010-10-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DJ COOPER ENTERPRISES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-09-05) - LIQ02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-13) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-13) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-19) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-27) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-28) - AP01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-09-05) - 600
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-25) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-25) - PSC01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-09) - AD01
-
resolution (2019-09-05) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-03-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-26) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-02-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-23) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-29) - CS01
-
resolution (2017-11-28) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-28) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-28) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-28) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-28) - PSC07
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-10-11) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-10-03) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-12-03) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-30) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2016-10-04) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-01-23) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-22) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-22) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2016-01-12) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-12) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-17) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-23) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-07-12) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-06-12) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-10-18) - NEWINC