-
KIMA ARCHITECTURE & INTERIORS LTD - Third Floor, 112 Clerkenwell Road, London, EC1M 5SA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07409637
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Third Floor
- 112 Clerkenwell Road
- London
- EC1M 5SA Third Floor, 112 Clerkenwell Road, London, EC1M 5SA UK
Management
- Geschäftsführung
- GONCHAROVA, Karina
- ROCCHETTI, Claudio
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.10.2010
- Gelöscht am:
- 2020-07-25
- SIC/NACE
- 71111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Miss Karina Goncharova
- Mr Claudio Rocchetti
- Ms. Karina Goncharova
- Mr Claudio Rocchetti
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- KIMA ARCHITECTURE LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-25
-
KIMA ARCHITECTURE & INTERIORS LTD Firmenbeschreibung
- KIMA ARCHITECTURE & INTERIORS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07409637. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 15.10.2010 registriert. KIMA ARCHITECTURE & INTERIORS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen KIMA ARCHITECTURE LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71111" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.03.2013.Die Firma kann schriftlich über Third Floor erreicht werden.
Jetzt sichern KIMA ARCHITECTURE & INTERIORS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kima Architecture & Interiors Ltd - Third Floor, 112 Clerkenwell Road, London, EC1M 5SA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KIMA ARCHITECTURE & INTERIORS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-07-25) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-04-25) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2019-11-19) - LIQ10
-
liquidation-disclaimer-notice (2019-04-25) - NDISC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-04) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-03-03) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-03-03) - 600
-
resolution (2019-03-03) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-11-19) - 600
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-06) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-20) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-12) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-31) - AA
-
resolution (2016-06-22) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2016-06-22) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-20) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2016-04-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-07) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-04-07) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-07) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-11) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-09) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-06-27) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-07) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-26) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-03-25) - CH01
-
capital-allotment-shares (2011-03-14) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-01-28) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-21) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-11-18) - AA01
-
incorporation-company (2010-10-15) - NEWINC