-
CHESTERFIELD WT CONSULTANTS LTD - Mccabe Ford Williams Bank Chambers, 61 High Street, Cranbrook, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07402585
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Mccabe Ford Williams Bank Chambers
- 61 High Street
- Cranbrook
- Kent
- TN17 3EG Mccabe Ford Williams Bank Chambers, 61 High Street, Cranbrook, Kent, TN17 3EG UK
Management
- Geschäftsführung
- KING, Paul Michael
- O'LEARY, Shaun James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.10.2010
- Alter der Firma 2010-10-11 13 Jahre
- SIC/NACE
- 71200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paul Michael John King
- -
- -
- Shaun O'Leary
- Paul Michael John King
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- GROWDAWN LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-10-25
- Letzte Einreichung: 2022-10-11
-
CHESTERFIELD WT CONSULTANTS LTD Firmenbeschreibung
- CHESTERFIELD WT CONSULTANTS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07402585. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.10.2010 registriert. CHESTERFIELD WT CONSULTANTS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GROWDAWN LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71200" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Mccabe Ford Williams Bank Chambers erreicht werden.
Jetzt sichern CHESTERFIELD WT CONSULTANTS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Chesterfield Wt Consultants Ltd - Mccabe Ford Williams Bank Chambers, 61 High Street, Cranbrook, Kent, Grossbritannien
- 2010-10-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHESTERFIELD WT CONSULTANTS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
memorandum-articles (2023-04-20) - MA
-
resolution (2023-04-15) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2023-03-16) - SH02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-02-16) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-02-16) - PSC04
-
resolution (2023-05-13) - RESOLUTIONS
-
resolution (2023-04-20) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-11-16) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-03-29) - MR01
-
resolution (2021-07-23) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-07-07) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-07-07) - TM02
-
capital-return-purchase-own-shares (2021-08-13) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2021-08-13) - SH06
-
resolution (2021-09-05) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-11-08) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-10-11) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-10) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-10-22) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-12) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-24) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-16) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-24) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-15) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-16) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-09) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-17) - MR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-11-13) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-19) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-22) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-04) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-06-24) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2011-06-24) - TM02
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-11-22) - AA01
-
change-of-name-notice (2010-12-21) - CONNOT
-
incorporation-company (2010-10-11) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2010-12-21) - CERTNM