-
PURISM PROPERTIES LIMITED - Foxburgh, Warren Rise, New Malden, KT3 4SJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07383420
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Foxburgh
- Warren Rise
- New Malden
- KT3 4SJ
- England Foxburgh, Warren Rise, New Malden, KT3 4SJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GREENHALGH, Alan David John
- GREENHALGH, Philip William
- GREENHALGH, Robin David Vincent
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-21 14 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- DUPLO PROPERTY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-02-28
- Letzte Einreichung: 2023-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-21
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-05
- Letzte Einreichung: 2023-09-21
-
PURISM PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- PURISM PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07383420. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.09.2010 registriert. PURISM PROPERTIES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DUPLO PROPERTY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Foxburgh erreicht werden.
Jetzt sichern PURISM PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Purism Properties Limited - Foxburgh, Warren Rise, New Malden, KT3 4SJ, Grossbritannien
- 2010-09-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PURISM PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-09-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-09-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-11-01) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-05-19) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-05-19) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-12) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-02-12) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-24) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-02) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-05-08) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-27) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-09-12) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-09-04) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-01-25) - PSC08
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-08-17) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-04) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-17) - PSC07
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-20) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-11-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-12) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
miscellaneous (2013-09-10) - MISC
-
auditors-resignation-company (2013-09-18) - AUD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-11) - AR01
-
legacy (2013-02-27) - MG02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-14) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-10-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-17) - AR01
-
legacy (2012-06-15) - MG01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-05-15) - AD01
-
legacy (2012-04-13) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-11-11) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-13) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-10-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-12-24) - MG01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-29) - CH01
-
incorporation-company (2010-09-21) - NEWINC