-
DEIGHTON PIERCE GLYNN LIMITED - 382, City Road City Road, London, EC1V 2QA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07382358
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 382
- City Road City Road
- London
- EC1V 2QA
- England 382, City Road City Road, London, EC1V 2QA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- EGGLETON, Joanna
- GLYNN, Polly
- HUNDT, Adam
- RICCA, Sarah Caroline
- THOMSON, Joanna
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-21 13 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Sarah Caroline Ricca
- Ms Polly Glynn
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PIERCE GLYNN LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-09-21
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-05
- Letzte Einreichung: 2020-09-21
-
DEIGHTON PIERCE GLYNN LIMITED Firmenbeschreibung
- DEIGHTON PIERCE GLYNN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07382358. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.09.2010 registriert. DEIGHTON PIERCE GLYNN LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PIERCE GLYNN LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/11/2010 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.09.2014.Die Firma kann schriftlich über 382 erreicht werden.
Jetzt sichern DEIGHTON PIERCE GLYNN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Deighton Pierce Glynn Limited - 382, City Road City Road, London, EC1V 2QA, Grossbritannien
- 2010-09-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DEIGHTON PIERCE GLYNN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
second-filing-of-director-termination-with-name (2020-11-24) - RP04TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-15) - TM01
-
capital-allotment-shares (2020-05-06) - SH01
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-10-07) - SH03
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2020-10-29) - SH10
-
capital-cancellation-shares (2020-10-07) - SH06
-
resolution (2020-10-15) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-01) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-04) - CS01
-
memorandum-articles (2020-10-15) - MA
keyboard_arrow_right 2019
-
capital-allotment-shares (2019-08-14) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-09-16) - SH08
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-25) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-05) - AP01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-10-29) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-11-01) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-11) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-29) - PSC01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-01) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-02) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-10-02) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-return-purchase-own-shares (2016-11-29) - SH03
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-03) - AA
-
capital-cancellation-shares (2016-11-29) - SH06
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-14) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-19) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-30) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-30) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-19) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-21) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-of-name-notice (2012-05-02) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2012-05-02) - CERTNM
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-10-16) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-05) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-04-12) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-04-08) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-04-06) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-09-22) - AD01
-
incorporation-company (2010-09-21) - NEWINC