-
ENABLE BY DESIGN LTD - C/O Poppleton & Appleby The Media Centre, 7 Northumberland Street, Huddersfield, HD1 1RL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07378026
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Poppleton & Appleby The Media Centre
- 7 Northumberland Street
- Huddersfield
- HD1 1RL
- United Kingdom C/O Poppleton & Appleby The Media Centre, 7 Northumberland Street, Huddersfield, HD1 1RL, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BATSON, Stephen Mark
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.09.2010
- Gelöscht am:
- 2022-01-06
- SIC/NACE
- 71111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Gary Lee Shuckford
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- BOWMAN RILEY HEALTHCARE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-16
-
ENABLE BY DESIGN LTD Firmenbeschreibung
- ENABLE BY DESIGN LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07378026. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 16.09.2010 registriert. ENABLE BY DESIGN LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BOWMAN RILEY HEALTHCARE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71111" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.09.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o Poppleton & Appleby The Media Centre erreicht werden.
Jetzt sichern ENABLE BY DESIGN LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Enable By Design Ltd - C/O Poppleton & Appleby The Media Centre, 7 Northumberland Street, Huddersfield, HD1 1RL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ENABLE BY DESIGN LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
gazette-dissolved-liquidation (2022-01-06) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-10-06) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-12-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-12-04) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-12-13) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-21) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-21) - CS01
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2017-09-22) - AD02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-22) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-03) - AD01
-
resolution (2017-11-14) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-11-14) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2017-11-14) - LIQ02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-of-name-notice (2016-09-08) - CONNOT
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-25) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-02) - CS01
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2016-11-02) - AD02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2016-09-08) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-21) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-22) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-17) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-10-08) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-22) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-18) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-13) - AA
-
capital-allotment-shares (2012-10-03) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
move-registers-to-sail-company (2011-12-13) - AD03
-
change-sail-address-company (2011-12-13) - AD02
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-13) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-14) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-09-22) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-09-21) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-01-17) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-12-01) - AP03
-
incorporation-company (2010-09-16) - NEWINC