-
MANDEVCO INTERNATIONAL LTD. - 3 Rotherbrook Court, Bedford Road, Petersfield, GU32 3QG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07377201
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3 Rotherbrook Court
- Bedford Road
- Petersfield
- GU32 3QG
- England 3 Rotherbrook Court, Bedford Road, Petersfield, GU32 3QG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- NUGENT, Graham Leslie
- O'SULLIVAN, Patrick Donnell
- Prokuristen
- LEX SECRETARIES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-15 13 Jahre
- SIC/NACE
- 78300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Patrick Donnell O'Sullivan
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- TOASTIES LTD.
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-09-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-12-04
- Letzte Einreichung: 2019-11-20
-
MANDEVCO INTERNATIONAL LTD. Firmenbeschreibung
- MANDEVCO INTERNATIONAL LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07377201. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.09.2010 registriert. MANDEVCO INTERNATIONAL LTD. hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen TOASTIES LTD. ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78300" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.09.2014.Die Firma kann schriftlich über 3 Rotherbrook Court erreicht werden.
Jetzt sichern MANDEVCO INTERNATIONAL LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mandevco International Ltd. - 3 Rotherbrook Court, Bedford Road, Petersfield, GU32 3QG, Grossbritannien
- 2010-09-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MANDEVCO INTERNATIONAL LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-05-01) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-08-02) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-02) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-05-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-23) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-11) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-28) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-01-25) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-02) - PSC01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2018-03-28) - CH04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-03-08) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-29) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-29) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-13) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-07) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-27) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-03) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-05-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-06) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2012-07-24) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2012-07-24) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-03-13) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-20) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-09-19) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-10-11) - AA01
-
incorporation-company (2010-09-15) - NEWINC