-
BUSINESS COMMS SOLUTION LIMITED - 2 Hardman Street, Manchester, M3 3HF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07376869
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Hardman Street
- Manchester
- M3 3HF 2 Hardman Street, Manchester, M3 3HF UK
Management
- Geschäftsführung
- DOHERTY, Paul Nicholas
- EARLE, Christopher James
- Prokuristen
- HILL, Gillian Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-15 13 Jahre
- SIC/NACE
- 61900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Verastar Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-01-31
- Letzte Einreichung: 2017-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-06-07
- Letzte Einreichung: 2019-05-24
-
BUSINESS COMMS SOLUTION LIMITED Firmenbeschreibung
- BUSINESS COMMS SOLUTION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07376869. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.09.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.09.2012.Die Firma kann schriftlich über 2 Hardman Street erreicht werden.
Jetzt sichern BUSINESS COMMS SOLUTION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Business Comms Solution Limited - 2 Hardman Street, Manchester, M3 3HF, Grossbritannien
- 2010-09-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BUSINESS COMMS SOLUTION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-06) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-30) - CS01
-
resolution (2019-08-25) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-09-09) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-27) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-08-25) - LIQ01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-02-05) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-04-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-10) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-03-10) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-10) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-03-10) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-10) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2015-11-12) - DISS16(SOAS)
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-11-28) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-25) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2015-10-06) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-11-20) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-19) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2013-10-01) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-24) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-05-24) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-24) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
gazette-notice-compulsary (2012-01-17) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-10) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-02-11) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-17) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-09-18) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2012-09-11) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-10-23) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-23) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2010-09-16) - TM01
-
incorporation-company (2010-09-15) - NEWINC