-
OH ACQUISITIONS LIMITED - 14 Hartington Place, Carlisle, CA1 1HL, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07365943
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 14 Hartington Place
- Carlisle
- CA1 1HL
- England 14 Hartington Place, Carlisle, CA1 1HL, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HOLLIDAY, Sandra Dawn
- SCANLAN, Ian Philip
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-06 13 Jahre
- SIC/NACE
- 86900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Sandra Dawn Holliday
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-20
- Letzte Einreichung: 2023-09-06
-
OH ACQUISITIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- OH ACQUISITIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07365943. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.09.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.09.2012.Die Firma kann schriftlich über 14 Hartington Place erreicht werden.
Jetzt sichern OH ACQUISITIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Oh Acquisitions Limited - 14 Hartington Place, Carlisle, CA1 1HL, England, Grossbritannien
- 2010-09-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OH ACQUISITIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-05-01) - AP01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-09-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-12-01) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-11-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-11-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-07-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-14) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-10-05) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-14) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-13) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-09-07) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-01) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-05-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-11-01) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-10-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-10-14) - CH01
-
capital-allotment-shares (2011-10-13) - SH01
-
resolution (2011-10-13) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-10-03) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-09-29) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2011-08-17) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-09-06) - NEWINC