-
HARTFORD CARE (2) LIMITED - 2nd, Floor Clifton House, Bunnian Place, Basingstoke, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07358700
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd
- Floor Clifton House
- Bunnian Place
- Basingstoke
- Hampshire
- RG21 7JE 2nd, Floor Clifton House, Bunnian Place, Basingstoke, Hampshire, RG21 7JE UK
Management
- Geschäftsführung
- GAVIN, Joanna Lesley
- GAVIN, Sean Francis
- SMITH, Amanda Helen
- SMITH, Leah-Marie Shirley Jean
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.08.2010
- Alter der Firma 2010-08-27 13 Jahre
- SIC/NACE
- 87300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Whites Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- HARTFORD CARE (NORTHERN) LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800DTXC78IMO9BK02
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-27
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-09-10
- Letzte Einreichung: 2020-08-27
-
HARTFORD CARE (2) LIMITED Firmenbeschreibung
- HARTFORD CARE (2) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07358700. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.08.2010 registriert. HARTFORD CARE (2) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HARTFORD CARE (NORTHERN) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87300" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 27.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 2Nd erreicht werden.
Jetzt sichern HARTFORD CARE (2) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hartford Care (2) Limited - 2nd, Floor Clifton House, Bunnian Place, Basingstoke, Grossbritannien
- 2010-08-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HARTFORD CARE (2) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-28) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-02-03) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-01-29) - MR04
-
resolution (2020-02-14) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-02-14) - MA
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-12-04) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-06) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-29) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-29) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-09-11) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-05) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-06) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-11-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-31) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-29) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-06) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-14) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-09-06) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-12-18) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-12) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-01) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-28) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-25) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-12-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-04) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-04-02) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-01-18) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-02-10) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-02-10) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-08-29) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-12-20) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-09) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-10-11) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-11) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2011-06-14) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-08-27) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2010-09-25) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-09-25) - AP01