-
J C SOLICITORS LIMITED - Jc Solicitors, 15 Southgate, Chichester, West Sussex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07354768
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Jc Solicitors
- 15 Southgate
- Chichester
- West Sussex
- PO19 1ES
- England Jc Solicitors, 15 Southgate, Chichester, West Sussex, PO19 1ES, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DE SILVA, Jacqui Helen
- JEFFERY, Tania Mercedes
- Prokuristen
- JEFFERY, Graham
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.08.2010
- Alter der Firma 2010-08-24 13 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Tania Mercedes Jeffery
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-13
- Letzte Einreichung: 2020-10-30
-
J C SOLICITORS LIMITED Firmenbeschreibung
- J C SOLICITORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07354768. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.08.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Jc Solicitors erreicht werden.
Jetzt sichern J C SOLICITORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: J C Solicitors Limited - Jc Solicitors, 15 Southgate, Chichester, West Sussex, Grossbritannien
- 2010-08-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu J C SOLICITORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-17) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-30) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-04-02) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-02) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-03) - PSC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-05) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-02-05) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-06) - AP01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2018-03-05) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-03-05) - CH01
-
change-person-director-company (2018-03-07) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-07) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-05) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-18) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-07) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-07) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-10) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-29) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-13) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-15) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-20) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-22) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-26) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-10-26) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-26) - AD01
-
incorporation-company (2010-08-24) - NEWINC