-
RAPIDSCAN PHARMA SOLUTIONS EU LIMITED - Pollards Wood, Nightingales Lane, Chalfont St. Giles, Buckinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07348627
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Pollards Wood
- Nightingales Lane
- Chalfont St. Giles
- Buckinghamshire
- HP8 4SP
- United Kingdom Pollards Wood, Nightingales Lane, Chalfont St. Giles, Buckinghamshire, HP8 4SP, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- JONES, Katherine Ann
- NARAYAN, Adrian Ashwin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.08.2010
- Alter der Firma 2010-08-17 13 Jahre
- SIC/NACE
- 77400
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- General Electric Company
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-31
- Letzte Einreichung: 2020-08-17
-
RAPIDSCAN PHARMA SOLUTIONS EU LIMITED Firmenbeschreibung
- RAPIDSCAN PHARMA SOLUTIONS EU LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07348627. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.08.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "77400" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Pollards Wood erreicht werden.
Jetzt sichern RAPIDSCAN PHARMA SOLUTIONS EU LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rapidscan Pharma Solutions Eu Limited - Pollards Wood, Nightingales Lane, Chalfont St. Giles, Buckinghamshire, Grossbritannien
- 2010-08-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RAPIDSCAN PHARMA SOLUTIONS EU LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-08-17) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-05-21) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-06-29) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-04-07) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-02-13) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-28) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-15) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-04-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-29) - CS01
-
move-registers-to-registered-office-company-with-new-address (2019-04-15) - AD04
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-12-11) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-04-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-13) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-28) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-27) - PSC02
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-09-05) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-23) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-23) - CH01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2017-08-02) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2017-08-02) - AD02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-18) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-08-28) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-24) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-04) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-09-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-17) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-05-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-08) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-08-19) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-10-04) - AP01
-
incorporation-company (2010-08-17) - NEWINC