-
64 & 66 PEMBROKE ROAD LIMITED - Nightingale House, 46-48 East Street, Epsom, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07341733
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Nightingale House
- 46-48 East Street
- Epsom
- Surrey
- KT17 1HQ Nightingale House, 46-48 East Street, Epsom, Surrey, KT17 1HQ UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIES, Paul Duffield
- FERGUSON, Meyrick Edward Douglas
- SAWER, James Matthew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.08.2010
- Gelöscht am:
- 2020-03-17
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Sheila Helen Elizabeth Dowling
- Mrs Patricia Ann Margaret Lord
- Mr Hugh John Meyrick Ferguson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2019-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-10
-
64 & 66 PEMBROKE ROAD LIMITED Firmenbeschreibung
- 64 & 66 PEMBROKE ROAD LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07341733. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.08.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.08.2012.Die Firma kann schriftlich über Nightingale House erreicht werden.
Jetzt sichern 64 & 66 PEMBROKE ROAD LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 64 & 66 Pembroke Road Limited - Nightingale House, 46-48 East Street, Epsom, Surrey, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 64 & 66 PEMBROKE ROAD LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-03-17) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-12) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-02) - TM01
-
gazette-notice-voluntary (2019-12-31) - GAZ1(A)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-11) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2019-12-18) - DS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-12-06) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-19) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-24) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-24) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-23) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-23) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-02) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-02) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-22) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-08) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-08-28) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-04-17) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-08-12) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-08-10) - NEWINC