-
LSP ACQUISITION (UK) LTD - Universal Point, Steelmans Road, Wednesbury, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07319417
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Universal Point
- Steelmans Road
- Wednesbury
- West Midlands
- WS10 9UZ Universal Point, Steelmans Road, Wednesbury, West Midlands, WS10 9UZ UK
Management
- Geschäftsführung
- AINSWORTH, Jonathan
- DIAMOND, Steven John
- HOFFMAN, Alexander James William
- WILKINSON, Alan Walter
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.07.2010
- Alter der Firma 2010-07-20 13 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Lsp Investco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-08-03
- Letzte Einreichung: 2022-07-20
-
LSP ACQUISITION (UK) LTD Firmenbeschreibung
- LSP ACQUISITION (UK) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07319417. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.07.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Universal Point erreicht werden.
Jetzt sichern LSP ACQUISITION (UK) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lsp Acquisition (Uk) Ltd - Universal Point, Steelmans Road, Wednesbury, West Midlands, Grossbritannien
- 2010-07-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LSP ACQUISITION (UK) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-03-15) - MR04
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-09-23) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-09-24) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-05-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-14) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-12-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-09-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-08-01) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-10-27) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-01-14) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
miscellaneous (2015-01-05) - MISC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-22) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-28) - AR01
-
miscellaneous (2015-01-19) - MISC
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-09-22) - AA
-
resolution (2014-04-11) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2014-04-11) - MEM/ARTS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-04) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-03) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-04-03) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-09-10) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-05-15) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-08-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-12) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-01-19) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-07-20) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2010-09-10) - SH01
-
resolution (2010-09-10) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2010-09-10) - MEM/ARTS
-
termination-director-company-with-name (2010-09-10) - TM01
-
legacy (2010-09-17) - MG01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-09-10) - AD01
-
legacy (2010-09-15) - MG01