-
MATERIAL RECOVERY SOLUTIONS LIMITED - Wellesley House, 204 London Road, Waterlooville, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07316248
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Wellesley House
- 204 London Road
- Waterlooville
- Hampshire
- PO7 7AN Wellesley House, 204 London Road, Waterlooville, Hampshire, PO7 7AN UK
Management
- Geschäftsführung
- HUTCHINS JUNIOR, Ian
- Prokuristen
- ANDREWS, Rebecca Susan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.07.2010
- Gelöscht am:
- 2020-06-16
- SIC/NACE
- 46770
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Ian Hutchins
- Mr Ian Hutchins
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-04-30
- Letzte Einreichung: 2016-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-15
-
MATERIAL RECOVERY SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- MATERIAL RECOVERY SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07316248. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 15.07.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46770" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.07.2012.Die Firma kann schriftlich über Wellesley House erreicht werden.
Jetzt sichern MATERIAL RECOVERY SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Material Recovery Solutions Limited - Wellesley House, 204 London Road, Waterlooville, Hampshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MATERIAL RECOVERY SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-06-16) - GAZ2
-
liquidation-compulsory-completion (2020-03-16) - L64.07
keyboard_arrow_right 2017
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2017-11-11) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2017-10-10) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-06) - AA
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2017-11-15) - COCOMP
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-26) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-07) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-11) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-11-05) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-10-06) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-06) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-14) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-23) - AA
-
resolution (2015-12-03) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-25) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-11-16) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-13) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2013-11-12) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-24) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-15) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-08-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-24) - AP01
-
capital-allotment-shares (2010-08-17) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-16) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-08-16) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2010-07-22) - TM01
-
incorporation-company (2010-07-15) - NEWINC