-
LABEL PR LIMITED - 36 Park Row, Leeds, LS1 5JL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07316217
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 36 Park Row
- Leeds
- LS1 5JL 36 Park Row, Leeds, LS1 5JL UK
Management
- Geschäftsführung
- HARVEY-FRANKLIN, Stephen John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.07.2010
- Alter der Firma 2010-07-15 13 Jahre
- SIC/NACE
- 70210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Stephen John Harvey-Franklin
- Attercopia Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-12-30
- Letzte Einreichung: 2016-03-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-08-10
- Letzte Einreichung: 2017-07-27
-
LABEL PR LIMITED Firmenbeschreibung
- LABEL PR LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07316217. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.07.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70210" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 36 Park Row erreicht werden.
Jetzt sichern LABEL PR LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Label Pr Limited - 36 Park Row, Leeds, LS1 5JL, Grossbritannien
- 2010-07-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LABEL PR LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-02-19) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-02-27) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-10) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-01-06) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-01-06) - 600
-
resolution (2018-01-06) - RESOLUTIONS
-
liquidation-disclaimer-notice (2018-03-08) - NDISC
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-14) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-03) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-15) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-09-27) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-27) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-12-19) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-16) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-11-26) - MR04
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-06) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-19) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2015-05-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-22) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-22) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-07-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
legacy (2013-03-23) - MG01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-07-18) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-20) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-08-15) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-08) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-16) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-27) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-08-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-10-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-07-21) - TM01
-
incorporation-company (2010-07-15) - NEWINC