-
CUT FILMS LIMITED - Cotton Exchange, Old Hall Street, Liverpool, L3 9LQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07313137
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cotton Exchange
- Old Hall Street
- Liverpool
- L3 9LQ
- England Cotton Exchange, Old Hall Street, Liverpool, L3 9LQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GRUNDY, Michael Samuel
- CHADWICK, Paula Marie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.07.2010
- Alter der Firma 2010-07-13 13 Jahre
- SIC/NACE
- 88990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Roy Castle Lung Cancer Foundation
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- DHC ENTERPRISES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-11-04
- Letzte Einreichung: 2023-10-21
-
CUT FILMS LIMITED Firmenbeschreibung
- CUT FILMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07313137. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.07.2010 registriert. CUT FILMS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DHC ENTERPRISES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "88990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Cotton Exchange erreicht werden.
Jetzt sichern CUT FILMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cut Films Limited - Cotton Exchange, Old Hall Street, Liverpool, L3 9LQ, Grossbritannien
- 2010-07-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CUT FILMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-11-06) - CS01
-
legacy (2023-11-06) - GUARANTEE2
-
legacy (2023-11-06) - AGREEMENT2
-
legacy (2023-10-10) - PARENT_ACC
-
legacy (2023-10-10) - AGREEMENT2
-
legacy (2023-11-06) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-11-06) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-02-16) - PSC05
-
legacy (2022-09-30) - GUARANTEE2
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-02-16) - PSC07
-
legacy (2022-09-30) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2022-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-12-20) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-02-16) - PSC02
-
legacy (2022-09-30) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-07) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-07) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-17) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-31) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-02) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-09) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-18) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-02-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-12-24) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2015-08-13) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-12) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-12) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-12) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-30) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-12-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-11-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-01-24) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-01-12) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-07-13) - NEWINC