-
OZON SOLICITORS LIMITED - 1st Floor 1 Ashley Road, Altrincham, WA14 2DT, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07306416
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1st Floor 1 Ashley Road
- Altrincham
- WA14 2DT
- England 1st Floor 1 Ashley Road, Altrincham, WA14 2DT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- KWASNICK, Sefton
- LIPSON, Harry Louie
- OZON, Michael
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.07.2010
- Alter der Firma 2010-07-06 13 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Michael Ozon
- -
- -
- -
- Mr Michael Ozon
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-08-31
- Letzte Einreichung: 2020-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-20
- Letzte Einreichung: 2021-07-06
-
OZON SOLICITORS LIMITED Firmenbeschreibung
- OZON SOLICITORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07306416. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.07.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 1St Floor 1 Ashley Road erreicht werden.
Jetzt sichern OZON SOLICITORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ozon Solicitors Limited - 1st Floor 1 Ashley Road, Altrincham, WA14 2DT, England, Grossbritannien
- 2010-07-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OZON SOLICITORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-26) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-20) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-20) - PSC07
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-09-09) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-30) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-18) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-18) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-19) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-26) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-17) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
legacy (2014-12-05) - RPCH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-15) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-07-24) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-10-31) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-30) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-03-05) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-03) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-11-12) - TM01
-
gazette-notice-compulsary (2012-10-30) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-11-03) - AP01
-
incorporation-company (2010-07-06) - NEWINC