-
DAY'S ESTATES LTD - C/O Ency Associates Printware Court, Cumberland Business Centre, Portsmouth, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07300977
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Ency Associates Printware Court
- Cumberland Business Centre
- Portsmouth
- Hampshire
- PO5 1DS
- England C/O Ency Associates Printware Court, Cumberland Business Centre, Portsmouth, Hampshire, PO5 1DS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- REX, Paul Ashley
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.07.2010
- Alter der Firma 2010-07-01 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68310
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paul Ashley Rex
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-02-29
- Letzte Einreichung: 2018-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-01
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-12
- Letzte Einreichung: 2019-07-01
-
DAY'S ESTATES LTD Firmenbeschreibung
- DAY'S ESTATES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07300977. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.07.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68310" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 01.07.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o Ency Associates Printware Court erreicht werden.
Jetzt sichern DAY'S ESTATES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Day's Estates Ltd - C/O Ency Associates Printware Court, Cumberland Business Centre, Portsmouth, Hampshire, Grossbritannien
- 2010-07-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DAY'S ESTATES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-03-04) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2020
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-06-05) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-05) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-06-05) - CH01
-
gazette-notice-compulsory (2020-10-27) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-01) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-07-01) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-01) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-08-08) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-02-27) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-02-25) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-22) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-06-15) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-04-29) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-07) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-04) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-07-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-07-01) - NEWINC