-
FRESH EGO KID LIMITED - 93 Tabernacle Street, London, EC2A 4BA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07299689
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 93 Tabernacle Street
- London
- EC2A 4BA 93 Tabernacle Street, London, EC2A 4BA UK
Management
- Geschäftsführung
- KORKLIN, Selwyn Miles
- MANNIX, Joel Nathanael
- MORGAN, Marvin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.06.2010
- Gelöscht am:
- 2021-04-04
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Marvin Morgan
- Mr Selwyn Miles Korklin
- Mr Marvin Morgan
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-08-31
- Letzte Einreichung: 2016-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-10
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-07-14
- Letzte Einreichung: 2017-06-30
-
FRESH EGO KID LIMITED Firmenbeschreibung
- FRESH EGO KID LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07299689. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 30.06.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 93 Tabernacle Street erreicht werden.
Jetzt sichern FRESH EGO KID LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fresh Ego Kid Limited - 93 Tabernacle Street, London, EC2A 4BA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FRESH EGO KID LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-01-04) - LIQ14
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-04-04) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-11-06) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-11-07) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-29) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-27) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-02-12) - AA01
-
gazette-notice-voluntary (2018-05-22) - GAZ1(A)
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2018-06-09) - SOAS(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2018-05-10) - DS01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-09-19) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-09-19) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-24) - AD01
-
resolution (2018-09-19) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-04) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-04) - PSC01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-18) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-09) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-28) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-10-31) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-28) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2015-10-27) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-20) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-04) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-09-19) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-17) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-15) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-03-30) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-04-02) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-30) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-09-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-07) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-10-09) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-21) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-07-21) - CH01
-
capital-allotment-shares (2011-07-20) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-06-30) - NEWINC