-
IVYDALE PLANT LIMITED - 8a Kingsway House, King Street, Bedworth, Warwickshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07292942
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 8a Kingsway House
- King Street
- Bedworth
- Warwickshire
- CV12 8HY 8a Kingsway House, King Street, Bedworth, Warwickshire, CV12 8HY UK
Management
- Geschäftsführung
- BOYCE, James Gerard
- Prokuristen
- BOYCE, James Gerard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.06.2010
- Alter der Firma 2010-06-23 14 Jahre
- SIC/NACE
- 42990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr James Gerard Boyce
- Mrs Tracy Boyce
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-01-31
- Letzte Einreichung: 2018-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2015-06-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-07-07
- Letzte Einreichung: 2019-06-23
-
IVYDALE PLANT LIMITED Firmenbeschreibung
- IVYDALE PLANT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07292942. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.06.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "42990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.06.2015.Die Firma kann schriftlich über 8A Kingsway House erreicht werden.
Jetzt sichern IVYDALE PLANT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ivydale Plant Limited - 8a Kingsway House, King Street, Bedworth, Warwickshire, Grossbritannien
- 2010-06-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu IVYDALE PLANT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
resolution (2020-02-26) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-02-26) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-02-26) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-02-27) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-14) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-24) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-24) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-23) - AR01
-
second-filing-of-form-with-form-type (2016-04-21) - RP04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-28) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-01-12) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-04-28) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-04-24) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-24) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-28) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-05-07) - CH03
-
termination-secretary-company-with-name (2014-05-07) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-22) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-05-07) - AP03
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-06-06) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2014-05-07) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-01-17) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-03-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-12-05) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-04) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-02-04) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-04) - AP01
-
capital-allotment-shares (2011-02-04) - SH01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-06-23) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2010-06-28) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-28) - AD01