-
THE WOOD HEATING COMPANY (BIOMASS) LTD - Unit 7a Sleekburn Business Centre, Cambois, Blyth, NE24 1QQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07284786
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 7a Sleekburn Business Centre
- Cambois
- Blyth
- NE24 1QQ
- England Unit 7a Sleekburn Business Centre, Cambois, Blyth, NE24 1QQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BLAKELEY, Michael Antony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.06.2010
- Alter der Firma 2010-06-15 13 Jahre
- SIC/NACE
- 43220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Michael Antony Blakeley
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-13
- Letzte Einreichung: 2020-06-29
-
THE WOOD HEATING COMPANY (BIOMASS) LTD Firmenbeschreibung
- THE WOOD HEATING COMPANY (BIOMASS) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07284786. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.06.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43220" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Unit 7A Sleekburn Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern THE WOOD HEATING COMPANY (BIOMASS) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Wood Heating Company (Biomass) Ltd - Unit 7a Sleekburn Business Centre, Cambois, Blyth, NE24 1QQ, Grossbritannien
- 2010-06-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE WOOD HEATING COMPANY (BIOMASS) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-04-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-10) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-15) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-06-29) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-02-23) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-08-04) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-08-04) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-29) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-24) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-09) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-01) - CS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-01) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-04) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-13) - AA
-
resolution (2013-08-07) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-08-07) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-04) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-07-04) - CH01
-
move-registers-to-registered-office-company (2013-07-04) - AD04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-09) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-11-03) - SH01
-
resolution (2011-10-31) - RESOLUTIONS
-
resolution (2011-10-27) - RESOLUTIONS
-
move-registers-to-sail-company (2011-09-15) - AD03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-15) - AR01
-
change-sail-address-company (2011-07-13) - AD02
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-06-08) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-15) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-06-15) - NEWINC