-
TREF NO.2 LIMITED - C/O Temporis Capital Limited 7th Floor, Wellington House, 125 -130 Strand, London, WC2R 0AP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07283404
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Temporis Capital Limited 7th Floor, Wellington House
- 125 -130 Strand
- London
- WC2R 0AP
- England C/O Temporis Capital Limited 7th Floor, Wellington House, 125 -130 Strand, London, WC2R 0AP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WATSON, Sebastian Laurence Grenville
- HUBBARD, Matthew Richard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.06.2010
- Alter der Firma 2010-06-14 13 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- BOLSTERSTONE INNOVATIVE ENERGY (HAWTON) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-26
- Letzte Einreichung: 2020-06-12
-
TREF NO.2 LIMITED Firmenbeschreibung
- TREF NO.2 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07283404. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.06.2010 registriert. TREF NO.2 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BOLSTERSTONE INNOVATIVE ENERGY (HAWTON) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.06.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o Temporis Capital Limited 7Th Floor, Wellington House erreicht werden.
Jetzt sichern TREF NO.2 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tref No.2 Limited - C/O Temporis Capital Limited 7th Floor, Wellington House, 125 -130 Strand, London, WC2R 0AP, Grossbritannien
- 2010-06-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TREF NO.2 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-02-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-11-16) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-03-25) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-07) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-09-16) - PSC08
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-09-06) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-14) - CS01
-
legacy (2019-03-25) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2019-03-25) - SH19
-
legacy (2019-03-25) - CAP-SS
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-08-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-06-27) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-27) - PSC02
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-04-12) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-09-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-08) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-08) - TM01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-04-12) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-08) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2016-01-12) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-07) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-25) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-06) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-09-08) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-09-08) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-director-company-with-name (2010-06-22) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-06-22) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-22) - AD01
-
incorporation-company (2010-06-14) - NEWINC