-
HARROW SERVICED OFFICES LIMITED - Lillibrooke Manor Ockwells Road, Cox Green, Maidenhead, SL6 3LP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07279302
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Lillibrooke Manor Ockwells Road
- Cox Green
- Maidenhead
- SL6 3LP Lillibrooke Manor Ockwells Road, Cox Green, Maidenhead, SL6 3LP UK
Management
- Geschäftsführung
- ALBERTO, David Arthur Vere
- EVANS, Geraint Wyn
- KINNAIRD, David James
- Prokuristen
- ALEXANDER, Paul
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.06.2010
- Gelöscht am:
- 2022-04-26
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Arthur Vere Alberto
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- AVANTA HARROW LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-26
- Letzte Einreichung: 2021-06-12
-
HARROW SERVICED OFFICES LIMITED Firmenbeschreibung
- HARROW SERVICED OFFICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07279302. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 09.06.2010 registriert. HARROW SERVICED OFFICES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AVANTA HARROW LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Lillibrooke Manor Ockwells Road erreicht werden.
Jetzt sichern HARROW SERVICED OFFICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Harrow Serviced Offices Limited - Lillibrooke Manor Ockwells Road, Cox Green, Maidenhead, SL6 3LP, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HARROW SERVICED OFFICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-09-02) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2021-08-31) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-01-02) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-02) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-08-23) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-08-23) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-28) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-02-22) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-dormant (2018-02-22) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-10-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-03-22) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-09-10) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-09-09) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2016-09-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-07-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-06) - AR01
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2015-07-06) - AD02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-07-01) - MR04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-05-16) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-11-05) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-19) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-26) - AR01
-
change-sail-address-company (2014-06-26) - AD02
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
certificate-change-of-name-company (2013-07-22) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-03-15) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-09-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-20) - AR01
-
legacy (2011-06-10) - MG01
-
legacy (2011-12-22) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-08-11) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-11) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-08-11) - AP03
-
incorporation-company (2010-06-09) - NEWINC