-
SOFA PARTNERS LTD - The Dairy Tripp Hill Farm Buildings, Fittleworth, Pulborough, West Sussex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07274034
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Dairy Tripp Hill Farm Buildings
- Fittleworth
- Pulborough
- West Sussex
- RH20 1ER The Dairy Tripp Hill Farm Buildings, Fittleworth, Pulborough, West Sussex, RH20 1ER UK
Management
- Geschäftsführung
- CUSSINS, Andrew James
- GROUT, Tracey
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.06.2010
- Alter der Firma 2010-06-04 13 Jahre
- SIC/NACE
- 47599
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Sofas & Stuff Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-18
- Letzte Einreichung: 2021-06-04
-
SOFA PARTNERS LTD Firmenbeschreibung
- SOFA PARTNERS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07274034. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.06.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47599" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Dairy Tripp Hill Farm Buildings erreicht werden.
Jetzt sichern SOFA PARTNERS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sofa Partners Ltd - The Dairy Tripp Hill Farm Buildings, Fittleworth, Pulborough, West Sussex, Grossbritannien
- 2010-06-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SOFA PARTNERS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-08-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-04) - CS01
-
legacy (2021-08-10) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-08-10) - PARENT_ACC
-
legacy (2021-08-10) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-04) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-26) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-05) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-18) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-27) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-19) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2013-01-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-04) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-18) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-03-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-07) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-02-07) - TM02
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-06-02) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-10-05) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-09-09) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2010-09-09) - SH08
-
resolution (2010-09-09) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-09-09) - AD01
-
incorporation-company (2010-06-04) - NEWINC