-
CONTRACT RECOVERY SOLUTIONS LIMITED - Omega Court, 350 Cemetery Road, Sheffield, S11 8FT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07264403
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Omega Court
- 350 Cemetery Road
- Sheffield
- S11 8FT
- England Omega Court, 350 Cemetery Road, Sheffield, S11 8FT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.05.2010
- Alter der Firma 2010-05-25 14 Jahre
- SIC/NACE
- 82911
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Timothy David Shore
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-02-28
- Letzte Einreichung: 2019-05-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-13
- Letzte Einreichung: 2020-02-27
-
CONTRACT RECOVERY SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- CONTRACT RECOVERY SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07264403. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.05.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82911" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.05.2012.Die Firma kann schriftlich über Omega Court erreicht werden.
Jetzt sichern CONTRACT RECOVERY SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Contract Recovery Solutions Limited - Omega Court, 350 Cemetery Road, Sheffield, S11 8FT, Grossbritannien
- 2010-05-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CONTRACT RECOVERY SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-11-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-12) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-07) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-02-27) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-21) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-11) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-17) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-20) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-13) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-06) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2014-09-11) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-09-11) - SH08
-
resolution (2014-09-11) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-03) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-15) - AA
-
legacy (2011-09-01) - MG02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-08-23) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-26) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-11) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2011-04-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-05-25) - NEWINC
-
legacy (2010-10-08) - MG01