-
ASPERS UK HOLDINGS LIMITED - 1 Hans Street, London, SW1X 0JD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07262042
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Hans Street
- London
- SW1X 0JD 1 Hans Street, London, SW1X 0JD UK
Management
- Geschäftsführung
- ASPINALL, John Damian Androcles
- NOBLE, Richard Anthony John
- TAYLOR, Daniel James Breden
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.05.2010
- Alter der Firma 2010-05-21 14 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ASPINALLS UK H LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-21
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-27
- Letzte Einreichung: 2021-05-13
-
ASPERS UK HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- ASPERS UK HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07262042. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.05.2010 registriert. ASPERS UK HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ASPINALLS UK H LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.05.2012.Die Firma kann schriftlich über 1 Hans Street erreicht werden.
Jetzt sichern ASPERS UK HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Aspers Uk Holdings Limited - 1 Hans Street, London, SW1X 0JD, Grossbritannien
- 2010-05-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ASPERS UK HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-12-15) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-13) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-04-06) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-23) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-08-14) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-12-16) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-02) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-14) - CS01
-
resolution (2019-04-08) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-03-12) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-30) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-19) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-07-21) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-13) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-12-15) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-05-06) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2016-05-06) - MA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-09) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-04) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-04-14) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-11-21) - AA
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-03-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-07-03) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-23) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-05-23) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-05-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-group (2013-04-05) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-group (2012-02-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-07-21) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-09) - AR01
-
legacy (2011-05-16) - MG02
-
termination-director-company-with-name (2011-01-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-07-05) - MG06
-
certificate-change-of-name-company (2010-11-09) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2010-11-09) - CONNOT
-
incorporation-company (2010-05-21) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-09-15) - AA01
-
legacy (2010-07-22) - MG01
-
legacy (2010-07-09) - MG01
-
resolution (2010-07-20) - RESOLUTIONS