-
KISS GYMS LTD - Wellington House, 57 Dyer Street, Cirencester, GL7 2PP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07253034
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Wellington House
- 57 Dyer Street
- Cirencester
- GL7 2PP Wellington House, 57 Dyer Street, Cirencester, GL7 2PP UK
Management
- Geschäftsführung
- MACKENZIE HILL, Rupert
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.05.2010
- Alter der Firma 2010-05-13 14 Jahre
- SIC/NACE
- 86900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Rupert Mackenzie Hill
- Mr Rupert Mackenzie Hill
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-07-31
- Letzte Einreichung: 2020-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-01-28
- Letzte Einreichung: 2022-01-14
-
KISS GYMS LTD Firmenbeschreibung
- KISS GYMS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07253034. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.05.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86900" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Wellington House erreicht werden.
Jetzt sichern KISS GYMS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kiss Gyms Ltd - Wellington House, 57 Dyer Street, Cirencester, GL7 2PP, Grossbritannien
- 2010-05-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KISS GYMS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-15) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-25) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-12-18) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-08-30) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-25) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-17) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-18) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-07) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-22) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-10) - AR01
-
accounts-amended-with-made-up-date (2014-03-28) - AAMD
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-01-28) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-24) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-01-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-10) - AA
-
legacy (2012-01-21) - MG01
-
legacy (2012-01-26) - MG01
-
capital-allotment-shares (2012-03-19) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-24) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-07-10) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-12) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-11-24) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-04) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-alter-shares-subdivision (2010-07-30) - SH02
-
incorporation-company (2010-05-13) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2010-10-01) - SH01
-
resolution (2010-10-01) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2010-07-30) - SH01
-
resolution (2010-07-30) - RESOLUTIONS