-
2BANDTV LIMITED - 635, Bath Road, Slough, Berkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07241439
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 635
- Bath Road
- Slough
- Berkshire
- SL1 6AE 635, Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 6AE UK
Management
- Geschäftsführung
- HORNE, Andrew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.05.2010
- Gelöscht am:
- 2020-03-17
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Tracy Jane Horne
- Mr Andrew Horne
- Mr Andrew Horne
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2018-05-01
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-04
-
2BANDTV LIMITED Firmenbeschreibung
- 2BANDTV LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07241439. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 04.05.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.05.2012.Die Firma kann schriftlich über 635 erreicht werden.
Jetzt sichern 2BANDTV LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 2Bandtv Limited - 635, Bath Road, Slough, Berkshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 2BANDTV LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-03-17) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-21) - AA
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2019-07-30) - CVA3
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2019-09-11) - LIQ MISC OC
-
gazette-notice-voluntary (2019-12-31) - GAZ1(A)
-
liquidation-voluntary-arrangement-completion (2019-12-06) - CVA4
-
dissolution-application-strike-off-company (2019-12-19) - DS01
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2019-09-11) - 1.1
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-08-24) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-04) - CS01
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2018-07-13) - CVA3
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-09-01) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-30) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-30) - PSC01
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2017-06-03) - 1.3
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-31) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-18) - TM01
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2016-06-13) - 1.3
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2016-01-28) - 1.1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-08) - AA
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2015-06-18) - 1.3
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-03) - AR01
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2014-05-12) - 1.1
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-02-05) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-06-14) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-06-12) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-12) - AD01
-
incorporation-company (2010-05-04) - NEWINC