-
EZE TALK RESIDENTIAL LTD - Global House, 60b Queen Street, Horsham, RH13 5AD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07240512
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Global House
- 60b Queen Street
- Horsham
- RH13 5AD
- England Global House, 60b Queen Street, Horsham, RH13 5AD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BARNETT, Carl Nigel
- BARNETT, Nigel Martin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.04.2010
- Alter der Firma 2010-04-30 14 Jahre
- SIC/NACE
- 61900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Telecom Acquisitions Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- SO TELECOM LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-02-28
- Letzte Einreichung: 2023-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-07
- Letzte Einreichung: 2023-08-24
-
EZE TALK RESIDENTIAL LTD Firmenbeschreibung
- EZE TALK RESIDENTIAL LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07240512. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.04.2010 registriert. EZE TALK RESIDENTIAL LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SO TELECOM LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 29/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 30.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Global House erreicht werden.
Jetzt sichern EZE TALK RESIDENTIAL LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Eze Talk Residential Ltd - Global House, 60b Queen Street, Horsham, RH13 5AD, Grossbritannien
- 2010-04-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EZE TALK RESIDENTIAL LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-06-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-06-07) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-02-27) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2024-02-28) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2024-06-07) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2024-06-07) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2024-06-07) - PSC02
keyboard_arrow_right 2023
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-10-17) - PSC05
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-02-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-10-05) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-10) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-11) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-24) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-08-24) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-21) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-08) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-30) - CS01
-
resolution (2019-09-26) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-25) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-28) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-08-07) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-08-07) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-02) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-03-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-30) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-02-19) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-07-03) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
gazette-notice-compulsary (2011-08-30) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-09-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-09-22) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-09-20) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-13) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2011-09-14) - DISS40
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-04-30) - NEWINC