-
ST JAMES DEVELOPMENTS (CITY) LIMITED - Grenville House 4, Grenville Avenue, Broxbourne, Herts, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07234369
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Grenville House 4
- Grenville Avenue
- Broxbourne
- Herts
- EN10 7DH Grenville House 4, Grenville Avenue, Broxbourne, Herts, EN10 7DH UK
Management
- Geschäftsführung
- ELMES, Andrew Edward
- FORDHAM, Alan James
- Prokuristen
- FORDHAM, Alan James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.04.2010
- Gelöscht am:
- 2021-11-16
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Andrew Edward Elmes
- Mr Alan James Fordham
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-07-30
- Letzte Einreichung: 2019-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-10
- Letzte Einreichung: 2021-04-26
-
ST JAMES DEVELOPMENTS (CITY) LIMITED Firmenbeschreibung
- ST JAMES DEVELOPMENTS (CITY) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07234369. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 26.04.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Grenville House 4 erreicht werden.
Jetzt sichern ST JAMES DEVELOPMENTS (CITY) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: St James Developments (City) Limited - Grenville House 4, Grenville Avenue, Broxbourne, Herts, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ST JAMES DEVELOPMENTS (CITY) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-27) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-08-20) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-08-31) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-09-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-07-23) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-16) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-15) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-15) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-05-15) - PSC09
-
dissolution-withdrawal-application-strike-off-company (2018-04-19) - DS02
-
gazette-notice-voluntary (2018-02-20) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2018-02-13) - DS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-01-15) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-09) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-13) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-05-26) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-11-18) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-14) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-07-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-08-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-13) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-01-20) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-06-04) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-05-25) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-05-25) - AD01
-
capital-allotment-shares (2010-05-24) - SH01
-
incorporation-company (2010-04-26) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2010-04-29) - TM01