-
GBE PROPERTY GROUP LIMITED - Seneca House Links Point, Amy Johnson Way, Blackpool, Lancashire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07231948
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Seneca House Links Point
- Amy Johnson Way
- Blackpool
- Lancashire
- FY4 2FF
- England Seneca House Links Point, Amy Johnson Way, Blackpool, Lancashire, FY4 2FF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BANGHAM, David
- CARTER, James Foreshaw
- Prokuristen
- BANGHAM, David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.04.2010
- Alter der Firma 2010-04-22 14 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Bangham
- Mr David Bangham
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ROCKWAY PROJECTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-02-28
- Letzte Einreichung: 2019-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-09-24
- Letzte Einreichung: 2019-09-10
-
GBE PROPERTY GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- GBE PROPERTY GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07231948. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.04.2010 registriert. GBE PROPERTY GROUP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ROCKWAY PROJECTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.05.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Seneca House Links Point erreicht werden.
Jetzt sichern GBE PROPERTY GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Gbe Property Group Limited - Seneca House Links Point, Amy Johnson Way, Blackpool, Lancashire, Grossbritannien
- 2010-04-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GBE PROPERTY GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-02-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-21) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-23) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-09-03) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-02-27) - AA
-
resolution (2019-12-24) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-05) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-02-27) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-02-28) - DISS40
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-03-20) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2018-03-20) - CH03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-29) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-26) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-10) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-10) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-10) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-03) - TM01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2017-08-12) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2017-07-11) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-05-17) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-01-31) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-10-13) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-09-14) - DISS40
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2016-09-09) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2016-07-19) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-04) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-16) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-19) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-05-19) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-05) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-29) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-01) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-10) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-21) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-07-09) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-05-20) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-01-24) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-23) - AR01
-
change-sail-address-company (2011-05-23) - AD02
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-07-08) - AP01
-
incorporation-company (2010-04-22) - NEWINC