-
ESPARTACO GP LIMITED - Resolve Partners Limited 22 York Buildings, John Adam Street, London, WC2N 6JU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07225977
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Resolve Partners Limited 22 York Buildings
- John Adam Street
- London
- WC2N 6JU Resolve Partners Limited 22 York Buildings, John Adam Street, London, WC2N 6JU UK
Management
- Geschäftsführung
- HARRISON, Matthew Colin
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.04.2010
- Gelöscht am:
- 2020-10-13
- SIC/NACE
- 64999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Matthew Colin Harrison
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- DE FACTO 1759 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-04-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-04-30
- Letzte Einreichung: 2017-04-16
-
ESPARTACO GP LIMITED Firmenbeschreibung
- ESPARTACO GP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07225977. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 16.04.2010 registriert. ESPARTACO GP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DE FACTO 1759 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.04.2013.Die Firma kann schriftlich über Resolve Partners Limited 22 York Buildings erreicht werden.
Jetzt sichern ESPARTACO GP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Espartaco Gp Limited - Resolve Partners Limited 22 York Buildings, John Adam Street, London, WC2N 6JU, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ESPARTACO GP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-10-13) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-06-25) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-07-13) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-06-06) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2019-03-04) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-03-04) - 600
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-27) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-27) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-04-20) - 600
-
resolution (2018-04-20) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2018-04-20) - LIQ01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-05) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-12-12) - TM02
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-09-07) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-08-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-10-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-09-08) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-08-22) - CH03
-
termination-director-company-with-name (2014-04-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-11) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-01-20) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-09-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-09-26) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-05-22) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2012-05-22) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-11) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-07-12) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-06-13) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-director-company-with-name (2010-06-24) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-06-24) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-24) - AD01
-
incorporation-company (2010-04-16) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-06-30) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-07-05) - AP03
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-07-15) - AA01
-
change-of-name-notice (2010-06-22) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2010-06-22) - CERTNM