-
WARWICKSHIRE COUNSELLING CENTRE - 12 Riversley Road, Nuneaton, Warwickshire, CV11 5QT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07223795
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 12 Riversley Road
- Nuneaton
- Warwickshire
- CV11 5QT 12 Riversley Road, Nuneaton, Warwickshire, CV11 5QT UK
Management
- Geschäftsführung
- DRINKWATER, Keith James
- MCKENZIE, John Bruce
- NEWBORN, Carol
- SONOTA, Goriola Olawale
- WILLIAMS, Emma
Firmendetails
- Geschäftszweig
- private-limited-guarant-nsc-limited-exemption
- Gründungsdatum
- 14.04.2010
- Alter der Firma 2010-04-14 14 Jahre
- SIC/NACE
- 86900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Carol Newborn
- Mr Keith James Drinkwater
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-28
- Letzte Einreichung: 2021-04-14
-
WARWICKSHIRE COUNSELLING CENTRE Firmenbeschreibung
- WARWICKSHIRE COUNSELLING CENTRE ist eine in Grossbritannien als private-limited-guarant-nsc-limited-exemption registrierte Firma mit der Register-Nr. 07223795. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.04.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86900" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.04.2012.Die Firma kann schriftlich über 12 Riversley Road erreicht werden.
Jetzt sichern WARWICKSHIRE COUNSELLING CENTRE HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Warwickshire Counselling Centre - 12 Riversley Road, Nuneaton, Warwickshire, CV11 5QT, Grossbritannien
- 2010-04-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WARWICKSHIRE COUNSELLING CENTRE aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-28) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-01) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-05-14) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-11) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-11) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-25) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-04-30) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-04-16) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-12-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2016-05-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-10-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-27) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2015-05-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2014-04-23) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-12-19) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-08-30) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2013-04-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-04-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-07-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2012-05-08) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-21) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2011-05-13) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-12) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-04-11) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
resolution (2010-07-16) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2010-04-14) - NEWINC
-
memorandum-articles (2010-06-25) - MEM/ARTS
-
resolution (2010-06-25) - RESOLUTIONS