-
SPINAL SURGICAL ASSOCIATES LTD - Lynton House, 7-12 Tavistock Square, London, WC1H 9BQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07209747
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Lynton House
- 7-12 Tavistock Square
- London
- WC1H 9BQ Lynton House, 7-12 Tavistock Square, London, WC1H 9BQ UK
Management
- Geschäftsführung
- NOORDEEN, Mohamed Hamza Hilali, Dr
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.03.2010
- Alter der Firma 2010-03-31 14 Jahre
- SIC/NACE
- 86220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dr Mohamed Hamza Hilali Noordeen
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- HILALI NOORDEEN LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-30
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-14
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
-
SPINAL SURGICAL ASSOCIATES LTD Firmenbeschreibung
- SPINAL SURGICAL ASSOCIATES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07209747. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 31.03.2010 registriert. SPINAL SURGICAL ASSOCIATES LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HILALI NOORDEEN LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86220" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Lynton House erreicht werden.
Jetzt sichern SPINAL SURGICAL ASSOCIATES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Spinal Surgical Associates Ltd - Lynton House, 7-12 Tavistock Square, London, WC1H 9BQ, Grossbritannien
- 2010-03-31
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SPINAL SURGICAL ASSOCIATES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-14) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-14) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-09-09) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-18) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-16) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-15) - AAMD
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-22) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-08-06) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-04) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2014-08-05) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-06-28) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-08-17) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-17) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2010-05-12) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2010-05-12) - CONNOT
-
termination-secretary-company-with-name (2010-04-08) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2010-04-08) - TM01
-
incorporation-company (2010-03-31) - NEWINC