-
AUTOTECH OF WANDSWORTH LTD - Suite 25 95 Miles Road, Mitcham, Surrey, CR4 3FH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07209054
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 25 95 Miles Road
- Mitcham
- Surrey
- CR4 3FH
- England Suite 25 95 Miles Road, Mitcham, Surrey, CR4 3FH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CHOUDHRY, Basharat Ullah
- ZAFAR, Imran
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.03.2010
- Alter der Firma 2010-03-30 14 Jahre
- SIC/NACE
- 45200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Imran Zafar
- Mr Basharat Ullah Choudhry
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-13
- Letzte Einreichung: 2023-06-29
-
AUTOTECH OF WANDSWORTH LTD Firmenbeschreibung
- AUTOTECH OF WANDSWORTH LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07209054. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.03.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45200" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 29.03.2012.Die Firma kann schriftlich über Suite 25 95 Miles Road erreicht werden.
Jetzt sichern AUTOTECH OF WANDSWORTH LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Autotech Of Wandsworth Ltd - Suite 25 95 Miles Road, Mitcham, Surrey, CR4 3FH, Grossbritannien
- 2010-03-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AUTOTECH OF WANDSWORTH LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2024-02-29) - PSC01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-07) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-10-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-04-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-30) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-07-16) - PSC06
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-16) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-27) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-04-11) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-04-09) - AA
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2020-03-14) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2020-03-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-13) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-13) - PSC03
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-09-20) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-19) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-09-19) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-09-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-20) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-19) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-01) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-22) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-01-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-12) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-03-30) - NEWINC