-
UTILITY CONNECTIONS LIMITED - 5200 Cinnabar Court Daresbury Park, Daresbury, Warrington, WA4 4GE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07208442
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5200 Cinnabar Court Daresbury Park
- Daresbury
- Warrington
- WA4 4GE
- England 5200 Cinnabar Court Daresbury Park, Daresbury, Warrington, WA4 4GE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- APPLETON, Graham Nigel Grant
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.03.2010
- Alter der Firma 2010-03-30 14 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Appleton Utility Holdings Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- GROCO 344 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-06-12
- Letzte Einreichung: 2024-05-29
-
UTILITY CONNECTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- UTILITY CONNECTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07208442. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.03.2010 registriert. UTILITY CONNECTIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GROCO 344 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 30.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 5200 Cinnabar Court Daresbury Park erreicht werden.
Jetzt sichern UTILITY CONNECTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Utility Connections Limited - 5200 Cinnabar Court Daresbury Park, Daresbury, Warrington, WA4 4GE, Grossbritannien
- 2010-03-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu UTILITY CONNECTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-05-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-05-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-06-06) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-06-22) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-29) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-06-25) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-25) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-25) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-25) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-25) - AA
-
resolution (2019-07-11) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-08) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-03) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-06) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-17) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-04-02) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-07-21) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-16) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-06-10) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-06-18) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-06-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-07-19) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-23) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-05-23) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-10-07) - AA01
-
capital-allotment-shares (2010-09-28) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-09-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-09-28) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-09-28) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2010-09-22) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2010-09-22) - CONNOT
-
incorporation-company (2010-03-30) - NEWINC