-
SOLUTION DYNAMICS (INTERNATIONAL) LIMITED - Lancaster Court, 8 Barnes Wallis Road, Fareham, PO15 5TU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07198517
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Lancaster Court
- 8 Barnes Wallis Road
- Fareham
- PO15 5TU
- England Lancaster Court, 8 Barnes Wallis Road, Fareham, PO15 5TU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BRAND, Patrick Michael
- WATTS, Suzanne Christina
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.03.2010
- Alter der Firma 2010-03-22 14 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-03-31
- Letzte Einreichung: 2023-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-14
- Letzte Einreichung: 2023-02-28
-
SOLUTION DYNAMICS (INTERNATIONAL) LIMITED Firmenbeschreibung
- SOLUTION DYNAMICS (INTERNATIONAL) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07198517. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.03.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Lancaster Court erreicht werden.
Jetzt sichern SOLUTION DYNAMICS (INTERNATIONAL) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Solution Dynamics (International) Limited - Lancaster Court, 8 Barnes Wallis Road, Fareham, PO15 5TU, Grossbritannien
- 2010-03-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SOLUTION DYNAMICS (INTERNATIONAL) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-01-12) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-23) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-19) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-04-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-04-13) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-09) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-07) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-24) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-15) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-20) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-07-03) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-11) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2011-08-06) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-03) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2011-07-26) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-10-05) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-03-29) - TM01
-
incorporation-company (2010-03-22) - NEWINC