-
BREWCHEM INTERNATIONAL LIMITED - Riverside House, Irwell Street, Manchester, M3 5EN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07192533
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Riverside House
- Irwell Street
- Manchester
- M3 5EN Riverside House, Irwell Street, Manchester, M3 5EN UK
Management
- Geschäftsführung
- GILLIES, Nicholas Mark
- HUGHES ARMSTRONG CORPORATE INVESTMENT PLC
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.03.2010
- Gelöscht am:
- 2020-02-20
- SIC/NACE
- 25990
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- NEWLIST LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-03-31
- Letzte Einreichung: 2013-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-17
-
BREWCHEM INTERNATIONAL LIMITED Firmenbeschreibung
- BREWCHEM INTERNATIONAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07192533. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 17.03.2010 registriert. BREWCHEM INTERNATIONAL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen NEWLIST LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "25990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.03.2012.Die Firma kann schriftlich über Riverside House erreicht werden.
Jetzt sichern BREWCHEM INTERNATIONAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Brewchem International Limited - Riverside House, Irwell Street, Manchester, M3 5EN, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BREWCHEM INTERNATIONAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-02-20) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-07-30) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-27) - AD01
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2019-11-20) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-07-29) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-miscellaneous (2017-08-10) - LIQ MISC
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-08-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-08-01) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2015-05-26) - 2.34B
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-04-08) - 2.16B
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2015-06-10) - 2.24B
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-06-09) - 600
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-01-25) - MR01
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2014-12-22) - 2.24B
-
liquidation-in-administration-proposals (2014-07-07) - 2.17B
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-06-21) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-03) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2014-06-02) - 2.12B
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-05-19) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-25) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-27) - AD01
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2014-07-24) - 2.23B
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-07-09) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-12-19) - AA01
-
appoint-corporate-director-company-with-name (2012-09-28) - AP02
-
termination-director-company-with-name (2012-09-28) - TM01
-
legacy (2012-06-30) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-23) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-11-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-director-company-with-name (2010-05-18) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-05-18) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-05-18) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-05-19) - CH01
-
certificate-change-of-name-company (2010-07-06) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2010-06-25) - CONNOT
-
capital-allotment-shares (2010-06-30) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-06-30) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-24) - AD01
-
incorporation-company (2010-03-17) - NEWINC