-
STOWE FAMILY LAW SERVICES LIMITED - The Old Court House, Raglan Street, Harrogate, North Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07176297
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Old Court House
- Raglan Street
- Harrogate
- North Yorkshire
- HG1 1LT The Old Court House, Raglan Street, Harrogate, North Yorkshire, HG1 1LT UK
Management
- Geschäftsführung
- FOWLIE, Kenneth John
- HAWKHEAD, Julian Jack
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.03.2010
- Alter der Firma 2010-03-03 14 Jahre
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Stowe Family Law Property Limited
- Stowe Family Law Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MAGENTA HOLDINGS 1973 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-03
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-17
- Letzte Einreichung: 2021-03-03
-
STOWE FAMILY LAW SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- STOWE FAMILY LAW SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07176297. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.03.2010 registriert. STOWE FAMILY LAW SERVICES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MAGENTA HOLDINGS 1973 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.03.2013.Die Firma kann schriftlich über The Old Court House erreicht werden.
Jetzt sichern STOWE FAMILY LAW SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Stowe Family Law Services Limited - The Old Court House, Raglan Street, Harrogate, North Yorkshire, Grossbritannien
- 2010-03-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STOWE FAMILY LAW SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-amended-with-accounts-type-full (2021-10-13) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-05) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-11-04) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-11-04) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-29) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-29) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-04) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-04) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-07-25) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-16) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-02) - PSC05
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-12-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-15) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-04) - AP01
-
resolution (2017-06-02) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-31) - AP01
-
resolution (2017-03-07) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-02-24) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-21) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-of-name-notice (2015-03-11) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2015-03-11) - CERTNM
-
resolution (2015-03-11) - RESOLUTIONS
-
reregistration-private-unlimited-to-private-limited-company (2015-03-11) - RR06
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2015-03-11) - SH19
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-04) - AA
-
re-registration-memorandum-articles (2015-03-11) - MAR
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-03-18) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-03-11) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2010-03-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-03-11) - AP01
-
incorporation-company (2010-03-03) - NEWINC