-
DROYLSDEN GLASS LIMITED - 42/56 Audenshaw Road, Audenshaw, Manchester, M34 5HJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07173979
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 42/56 Audenshaw Road
- Audenshaw
- Manchester
- M34 5HJ
- England 42/56 Audenshaw Road, Audenshaw, Manchester, M34 5HJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HOWLES, Darren
- SIDDALL, Karl
- THACKERAY, Kevin Christopher
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.03.2010
- Alter der Firma 2010-03-02 14 Jahre
- SIC/NACE
- 43342
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Kevin Christopher Thackeray
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-02
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-16
- Letzte Einreichung: 2021-03-02
-
DROYLSDEN GLASS LIMITED Firmenbeschreibung
- DROYLSDEN GLASS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07173979. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.03.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43342" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 02.03.2013.Die Firma kann schriftlich über 42/56 Audenshaw Road erreicht werden.
Jetzt sichern DROYLSDEN GLASS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Droylsden Glass Limited - 42/56 Audenshaw Road, Audenshaw, Manchester, M34 5HJ, Grossbritannien
- 2010-03-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DROYLSDEN GLASS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-01-05) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-01-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
memorandum-articles (2021-01-06) - MA
-
resolution (2021-01-06) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-23) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-01-06) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-02-26) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-02-24) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-04-22) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-02-24) - PSC04
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-31) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-31) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-12) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-20) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-06-12) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-13) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-03) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-20) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-03) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-20) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-19) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-28) - AA
-
resolution (2015-05-21) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-05-21) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-12) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-03-12) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-30) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2012-05-02) - SH08
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-26) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-12) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-05-02) - SH01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-04) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-03-04) - CH03
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-23) - CH01
-
incorporation-company (2010-03-02) - NEWINC