-
DECKERS HOSPITALITY GROUP LIMITED - Unit F, Royle Pennine Trading Estate, Lynroyle Way, Rochdale, OL11 3EX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07161009
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit F
- Royle Pennine Trading Estate, Lynroyle Way
- Rochdale
- OL11 3EX
- England Unit F, Royle Pennine Trading Estate, Lynroyle Way, Rochdale, OL11 3EX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BRIERLEY, Clifford
- BRIERLEY, Maxwell James
- WALLER, Andrew
- Prokuristen
- COSGROVE, Victoria
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.02.2010
- Alter der Firma 2010-02-17 14 Jahre
- SIC/NACE
- 46170
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Clifford Brierley
- Mr Clifford Brierley
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- THE CRIMBLE LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800Y2NQYI6SCIFH93
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-03
- Letzte Einreichung: 2021-02-17
-
DECKERS HOSPITALITY GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- DECKERS HOSPITALITY GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07161009. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.02.2010 registriert. DECKERS HOSPITALITY GROUP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen THE CRIMBLE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46170" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 02/04/2012 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit F erreicht werden.
Jetzt sichern DECKERS HOSPITALITY GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Deckers Hospitality Group Limited - Unit F, Royle Pennine Trading Estate, Lynroyle Way, Rochdale, OL11 3EX, Grossbritannien
- 2010-02-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DECKERS HOSPITALITY GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-06-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-06-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-20) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-11-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-05-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-06-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
auditors-resignation-company (2017-09-27) - AUD
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-06-23) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-03) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-08) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-11) - AR01
-
resolution (2016-03-16) - RESOLUTIONS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2016-03-16) - SH19
-
legacy (2016-03-16) - SH20
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-07-12) - AA
-
legacy (2016-03-16) - CAP-SS
keyboard_arrow_right 2015
-
legacy (2015-04-13) - AGREEMENT2
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-04-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-23) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-01-06) - CH03
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-02-24) - AA01
-
accounts-amended-with-accounts-type-group (2014-02-11) - AAMD
-
resolution (2014-08-19) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-12-09) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-05-08) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2013-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-group (2012-10-26) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-10-23) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2012-10-23) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-07) - AR01
-
legacy (2012-02-03) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-03-04) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2011-11-15) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-04-22) - SH01
-
legacy (2010-04-17) - MG01
-
certificate-change-of-name-company (2010-03-25) - CERTNM
-
resolution (2010-03-23) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-03-17) - AA01
-
incorporation-company (2010-02-17) - NEWINC